Reporte de Crédito en Estados Unidos
📊 El reporte crediticio contiene información para análisis de créditos con datos de personas y empresas en listas internacionales.
🌐 Incluye datos de personas y compañías en las listas OFAC, PEPs, políticos, Interpol, ONU, alertas y sanciones internacionales relacionadas con los Estados Unidos de América (U.S.A.)
MICHAEL DAVID MUMMERT
| Nombre : | MICHAEL DAVID MUMMERT | | País : | us | | Dirección : | INMATE NUMBER: 38011-509, U.S. PENITENTIARY, P.O. BOX 1000, LEAVENWORTH, 66048; INMATE NUMBER: 38011-509, U.S. PENITENTIARY, P.O. BOX 1000, LEAVENWORTH, KS, US, 66048 | | Sanciones : | 89 F.R. 20942 3/26/2024 - 2024-03-20 - 2032-11-29; Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security - 2024-03-20 - 2032-11-29 | | Fuente : | US BIS Denied Persons List; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2025-10-31T11:32:56 |
JAMES O. WILSON JR.
| Nombre : | JAMES O. WILSON JR. | | País : | us | | Dirección : | FAYETTEVILLE, GA 30214 | | Sanciones : | NonProcurement - 1988-12-22 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
YASIN M HUSSAIN
| Nombre : | YASIN M HUSSAIN | | Alias : | Yasin M. Hussain | | Fecha de nacimiento : | 1965-01-19 | | País : | us | | Dirección : | 11646 SUN CIRCLE WAY, COLUMBIA, MD 21044; 11646 Sun Circle Way, Columbia MD 21044 | | Sanciones : | 1128a1 - 1996-09-10; 1996-06-10 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US Maryland Sanctioned Providers | | Fecha : | 2026-01-06T21:57:01 |
ARNITA LEFF
| Nombre : | ARNITA LEFF | | Alias : | Arnita Cowan Leff | | Fecha de nacimiento : | 1953-06-27 | | País : | us | | Dirección : | 4100 ORANGEWOOD DRIVE, BEACHWOOD, OH 44122; BEACHWOOD, OH 44122 | | Sanciones : | 1128a1 - 2021-05-20; Excluded - 2019-10-29; Reciprocal - Active - 2021-05-20; Reciprocal - Active - 2021-06-30 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US Ohio Medicaid Excluded and Suspended Providers; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
HAWWK LLC
| Nombre : | HAWWK LLC | | País : | us | | Dirección : | 1417 LARSON STREET, BLOOMER, WI 54724 | | Sanciones : | Reciprocal - 2022-07-21 - 2022-07-14 - 2042-07-14 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
Kathleen J King
| Nombre : | Kathleen J King | | Fecha de nacimiento : | 1952-09-08 | | País : | us | | Dirección : | 9231 BELINDER ROAD, LEAWOOD, KS 66206; LEAWOOD, KS 66206; Leawood, KS 66206 | | Sanciones : | 1128b4 - 2017-05-18; Reciprocal - Active - 2017-05-18; Reciprocal - Active - 2017-07-28 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
AROB KOLNYANG
| Nombre : | AROB KOLNYANG | | País : | us | | Dirección : | MESQUITE, TX 75181 | | Sanciones : | Reciprocal - 2025-12-17 - 2030-12-16 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-02-20T08:00:53 |
EDINA SECURITY CONSULTANTS
| Nombre : | EDINA SECURITY CONSULTANTS | | País : | us | | Dirección : | 2161 UNIVERSITY AVE W, SAINT PAUL, MN 55114 | | Sanciones : | Reciprocal - 2019-07-11 - 2029-07-10 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
TOP NOTCH CONSTRUCTION
| Nombre : | TOP NOTCH CONSTRUCTION | | País : | us | | Dirección : | 8692 KINGFISHER LANE, MACEDONIA, OH 44056 | | Sanciones : | Reciprocal - 2016-09-02 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
Anthony Bamonte
| Nombre : | Anthony Bamonte | | Fecha de nacimiento : | 1976-09-18 | | País : | us | | Dirección : | 7857 E STATE ROAD 46, SUNMAN, IN 47041; SUNMAN, IN 47041 | | Sanciones : | 1128a1 - 2021-11-18; Excluded - 2022-08-09; Reciprocal - Active - 2021-11-18; Reciprocal - Active - 2021-12-30 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US Ohio Medicaid Excluded and Suspended Providers; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T21:57:01 |
RENEE MICHELE HAAS
| Nombre : | RENEE MICHELE HAAS | | Alias : | Renee M. Haas | | Fecha de nacimiento : | 1949-11-16 | | País : | us | | Dirección : | 5200 IRVINE BLVD, SPC 320, IRVINE, CA 92620; 5200 Irvine Blvd., Spc. 320, Irvine, CA, 92620-2057; IRVINE, CA 92620 | | Sanciones : | 1128b4 - 2014-05-20; 2014-05-20; Reciprocal - Active - 2014-05-20 | | Fuente : | US California Medicaid Suspended and ineligible providers; US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T21:57:01 |
Jeff D. Haslam
| Nombre : | Jeff D. Haslam | | País : | us | | Dirección : | Dothan, AL 36301 | | Sanciones : | 1992-04-13; NonProcurement - Active - 1993-06-27 | | Fuente : | US Alabama Medicaid Suspended Providers; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
Gina Cevene Webster
| Nombre : | Gina Cevene Webster | | Fecha de nacimiento : | 1956-05-18 | | País : | us | | Dirección : | MOBILE, AL 36689; P O BOX 8604, MOBILE, AL 36689 | | Sanciones : | 1128b4 - 2008-09-18; 2008-09-18; Reciprocal - Active - 2008-09-18 | | Fuente : | US Alabama Medicaid Suspended Providers; US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
VISHESH GIRI
| Nombre : | VISHESH GIRI | | País : | us | | Dirección : | GAITHERSBURG, MD 20882 | | Sanciones : | Reciprocal - 2023-05-16 - 2029-03-15 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
Labsource LLC
| Nombre : | Labsource LLC | | Alias : | Labsource, LLC | | País : | us | | Dirección : | Greenville, SC 29607 | | Sanciones : | 2022-08-25; Medicare Revocation - 2020-10-28; Terminated for Cause - 2025-10-03 | | Fuente : | US Kansas Medicaid Terminated Provider List; US New Hampshire Medicaid Exclusion and Sanction List; US South Carolina Excluded Providers | | Fecha : | 2025-11-01T04:35:02 |
Chen, Kan
| Nombre : | Chen, Kan | | Alias : | Kan Chen | | Fecha de nacimiento : | 1990-03 | | País : | us | | Sanciones : | ; ITAR Debarred (DTC) - State Department | | Fuente : | US Directorate of Defense Trade Controls AECA Debarments; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2025-09-11T08:44:03 |
CITADEL COMMUNITY DEVELOPMENT CORPORATION
| Nombre : | CITADEL COMMUNITY DEVELOPMENT CORPORATION | | Alias : | CITADEL COMMUNITY DEVELOPMENT CORP; CITADEL ECONOMIC DEVELOPMENT CORPORATION | | País : | us | | Dirección : | 568 N. MOUNTAIN VIEW AVENUE, SAN BERNARDINO, CA 92401 | | Sanciones : | Reciprocal - 2024-08-23 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
Just 4 Today Transportation
| Nombre : | Just 4 Today Transportation | | Alias : | JUST 4 TODAY TRANSPORTATION, INC | | País : | us | | Dirección : | 12600 Dove Ave, Cleveland, Ohio, OH, 44105; 12600 Dove, Cleveland, OH 44105 | | Sanciones : | Excluded - 2017-05-07 | | Fuente : | BrightQuery OpenData.org; US Ohio Medicaid Excluded and Suspended Providers | | Fecha : | 2026-02-07T03:05:11 |
Vision of Hope Providers LLC
| Nombre : | Vision of Hope Providers LLC | | País : | us | | Sanciones : | 2019-09-10 - 2029-09-10 | | Fuente : | US Nevada Medicaid Sanctions | | Fecha : | 2024-10-16T14:32:54 |
Nicole Maria Paulson
| Nombre : | Nicole Maria Paulson | | Fecha de nacimiento : | 1974-07-14 | | País : | us | | Dirección : | 1159 THOMAS AVENUE, SAN DIEGO, CA 92109; 6385 Cresthaven Dr., La Mesa, CA; SAN DIEGO, CA 92109 | | Sanciones : | 1128b4 - 2006-11-20; 2006-01-05; Reciprocal - Active - 2006-11-20 | | Fuente : | US California Medicaid Suspended and ineligible providers; US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
Carol Parker
| Nombre : | Carol Parker | | Fecha de nacimiento : | 1970-11-19 | | País : | us | | Dirección : | 6341 DREXEL ROAD, PHILADELPHIA, PA 19151; PHILADELPHIA, PA 19151; Philadelphia, PA | | Sanciones : | 1128a1 - 2015-02-19; Precluded - 2015-02-19; Reciprocal - Active - 2015-02-19 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US Pennsylvania Medicheck list; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T21:57:01 |
AYODEJI D FASONU
| Nombre : | AYODEJI D FASONU | | Alias : | FASONU, AYODEJI | | Fecha de nacimiento : | 1966-06-18 | | País : | us | | Dirección : | 70 RUSLING PLACE, BRIDGEPORT, CT 06604 | | Sanciones : | 1128a1 - 2025-06-19; 2023-02-07 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US New Jersey Ineligible Medicaid Providers | | Fecha : | 2026-01-06T21:57:01 |
EDEDEM EDEM
| Nombre : | EDEDEM EDEM | | Alias : | EDEDEM EKPENYONG EDEM | | Fecha de nacimiento : | 1977-05-10 | | País : | us | | Dirección : | 1307 BAKER ST, #JA04/1E3 43A, HOUSTON, TX 77002; 3295 FM 3514, #01782092, BEAUMONT, TX 77705; BEAUMONT, TX 77705; HOUSTON, TX 77002 | | Sanciones : | 1128a1 - 2008-12-18; 1128a1 - 2012-12-20; Reciprocal - Active - 2008-12-18; Reciprocal - Active - 2009-02-14; Reciprocal - Active - 2012-12-20 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
Antoine Cazeau
| Nombre : | Antoine Cazeau | | Fecha de nacimiento : | 1942-10-24 | | País : | us | | Dirección : | 31 SNOW AVE, APT 2, BROCKTON, MA 02401; Brockton, MA 02402 | | Sanciones : | 1128b1 - 1997-10-06; Reciprocal - Active - 1997-10-06; Reciprocal - Active - 1998-01-29 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
SANDRA ANN WHALEY
| Nombre : | SANDRA ANN WHALEY | | País : | us | | Dirección : | DES LOGE, MO 63601 | | Sanciones : | NonProcurement - 1992-11-20 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
THOMAS EARL NETTLES
| Nombre : | THOMAS EARL NETTLES | | País : | us | | Dirección : | MOSS POINT, MS 39563 | | Sanciones : | Reciprocal - 2024-11-22 - 2029-11-21 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
Darla Danae Gearhart
| Nombre : | Darla Danae Gearhart | | Fecha de nacimiento : | 1972-01-06 | | País : | us | | Dirección : | 100 COUNTY RD 429, JONESBORO, AR 72404; JONESBORO, AR 72404; Jonesboro, AR 72404 | | Sanciones : | ; 1128a3 - 2007-09-20; Reciprocal - Active - 2007-09-20 | | Fuente : | US Arkansas Medicaid Excluded Provider List; US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
CFK, INC
| Nombre : | CFK, INC | | País : | us | | Dirección : | 47 EAST 500 SOUTH, BOUNTIFUL, UT 84010 | | Sanciones : | 1128a3 - 2021-09-20; Reciprocal - Active - 2020-10-27 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
Joni James Tate
| Nombre : | Joni James Tate | | Fecha de nacimiento : | 1957-10-12 | | País : | us | | Dirección : | 1200 E MIDLAND AVE, #6-D, MUSCLE SHOALS, AL 35661; Muscle Shoals, AL 35661 | | Sanciones : | 1128b4 - 2000-05-18; 2000-05-18; Reciprocal - Active - 2000-05-18; Reciprocal - Active - 2000-09-19 | | Fuente : | US Alabama Medicaid Suspended Providers; US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
ANITA TREGO
| Nombre : | ANITA TREGO | | Alias : | TREGO-CAMPION, ANITA | | Fecha de nacimiento : | 1960-08-15 | | País : | us | | Dirección : | 136 S FELLOWSHIP RD, MAPLE SHADE, NJ 08052; 136 S. FELLOWSHIP ROAD, MAPLE SHADE, NJ 08052; MAPLE SHADE, NJ 08052 | | Sanciones : | 1128a3 - 2005-10-20; 2005-10-20; Reciprocal - Active - 2005-10-20; Reciprocal - Active - 2005-12-14 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US New Jersey Ineligible Medicaid Providers; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
JAMES R SIROIS
| Nombre : | JAMES R SIROIS | | Alias : | James R. Sirois | | Fecha de nacimiento : | 1950-04-25 | | País : | us | | Dirección : | 76 THIRD STREET, BANGOR, ME 04401; Bangor, ME 04401 | | Sanciones : | 1128b4 - 2003-09-19; 2003-09-29; Reciprocal - Active - 2003-09-19; Reciprocal - Active - 2003-11-25 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US Maine Medicaid Excluded Providers; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
Kathleen Etling Ennis
| Nombre : | Kathleen Etling Ennis | | Fecha de nacimiento : | 1965-11-26 | | País : | us | | Dirección : | 214 EAST 32ND ST, ERIE, PA 16504; ERIE, PA 16504; Erie, PA; Erie, PA 16504 | | Sanciones : | 1128b4 - 2004-06-17; Reciprocal - Active - 2004-06-17; Reciprocal - Active - 2004-08-19; Terminated - 2004-06-17 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US Pennsylvania Medicheck list; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
WANG HONGXING
| Nombre : | WANG HONGXING | | País : | us | | Sanciones : | 2021-11-11 | | Fuente : | US New York State Medicaid Exclusions | | Fecha : | 2024-09-03T17:05:05 |
KEITH SUTTON
| Nombre : | KEITH SUTTON | | País : | us | | Dirección : | FAYETTEVILLE, NC 28312 | | Sanciones : | Reciprocal - 2024-01-31 - 2026-09-19 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
Raynell Rankin
| Nombre : | Raynell Rankin | | Fecha de nacimiento : | 1965-12-07 | | País : | us | | Dirección : | 1240 S ROBERTSON ST, NEW ORLEANS, LA 70113; New Orleans, LA 70113 | | Sanciones : | 1128a1 - 2003-06-19; False Statements - 2003-01-31; Reciprocal - Active - 2003-08-21; Reciprocal - Active - 2003-09-25 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US Louisiana Department of Health Adverse Actions List; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
POSNER, ROBERT S.
| Nombre : | POSNER, ROBERT S. | | País : | us | | Dirección : | 53 WESTFIELD AVENUE, CLARK, NJ 07066 | | Sanciones : | 1999-06-23 | | Fuente : | US New Jersey Ineligible Medicaid Providers | | Fecha : | 2024-11-08T09:17:44 |
LETICIA KO CHY-KOA
| Nombre : | LETICIA KO CHY-KOA | | Fecha de nacimiento : | 1937-10-06 | | País : | us | | Dirección : | 3015 POLLY LANE, FLOSSMOOR, IL 60422; FLOSSMOOR, IL 60422 | | Sanciones : | 1128b4 - 2012-08-20; Reciprocal - Active - 2012-08-20; Reciprocal - Active - 2012-09-25 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T21:57:01 |
RYALL ANN MARIE LPN
| Nombre : | RYALL ANN MARIE LPN | | País : | us | | Sanciones : | 2011-09-26 | | Fuente : | US New York State Medicaid Exclusions | | Fecha : | 2025-03-20T17:05:05 |
Patricia Marie Melia
| Nombre : | Patricia Marie Melia | | Alias : | Melia, Patricia | | Fecha de nacimiento : | 1969-03-16 | | País : | us | | Dirección : | 15155 VENETIAN WAY, MORGAN HILL, CA 95037; 15155 Venetian Way, Morgan Hill, CA, 95037; MORGAN HILL, CA 95037 | | Sanciones : | 1128b4 - 2015-03-19; 2014-05-30; Reciprocal - Active - 2015-03-19 | | Fuente : | US California Medicaid Suspended and ineligible providers; US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T21:57:01 |
|